-
CERTUS SALES (UK) LIMITED - 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07900854
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 79 Caroline Street
- Birmingham
- B3 1UP 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP UK
Management
- Geschäftsführung
- BYRNE, Justin Matthew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.01.2012
- Gelöscht am:
- 2021-12-27
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Nomiti Ltd
- -
- -
- Certus Recruitment Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SANTA MONICA LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-28
- Letzte Einreichung: 2020-07-14
-
CERTUS SALES (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- CERTUS SALES (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07900854. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.01.2012 registriert. CERTUS SALES (UK) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SANTA MONICA LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 79 Caroline Street erreicht werden.
Jetzt sichern CERTUS SALES (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Certus Sales (Uk) Limited - 79 Caroline Street, Birmingham, B3 1UP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CERTUS SALES (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-11-05) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-08-05) - 600
-
resolution (2020-08-05) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-08-05) - LIQ02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-27) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-22) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-18) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-02-02) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-05) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-31) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-06) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-05-04) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-15) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-29) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-10-18) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-07-14) - MG01
-
legacy (2012-06-13) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-23) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-01-20) - AA01
-
incorporation-company (2012-01-06) - NEWINC