-
MANETO (UK) 3 LIMITED - Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07887920
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kingfield Road
- Coventry
- CV6 5AA Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA UK
Management
- Geschäftsführung
- BURKE, Patrick Kevin
- ELSBY-SMITH, Andrew
- IGO, Kevin Patrick
- SHELLEY, Jason Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-20 12 Jahre
- SIC/NACE
- 22290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Spalding Campbell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-22
- Letzte Einreichung: 2023-08-08
-
MANETO (UK) 3 LIMITED Firmenbeschreibung
- MANETO (UK) 3 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07887920. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Kingfield Road erreicht werden.
Jetzt sichern MANETO (UK) 3 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Maneto (Uk) 3 Limited - Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, Grossbritannien
- 2011-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MANETO (UK) 3 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-10-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-05-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-01-07) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-09-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-04-27) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-03) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-28) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-22) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-24) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-24) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-04) - TM02
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-08-03) - CH03
-
capital-allotment-shares (2012-03-26) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-15) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-03-15) - AP03
-
legacy (2012-03-15) - MG01
-
memorandum-articles (2012-02-20) - MEM/ARTS
-
resolution (2012-02-20) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-20) - NEWINC