-
SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED - Dsi Business Recovery Ashfield House, Illingworth St, Ossett, WF5 8AL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07872240
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dsi Business Recovery Ashfield House
- Illingworth St
- Ossett
- WF5 8AL Dsi Business Recovery Ashfield House, Illingworth St, Ossett, WF5 8AL UK
Management
- Geschäftsführung
- HUTCHINSON, Warren
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.12.2011
- Gelöscht am:
- 2021-02-26
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Tetyana Vovnyanko
- Mr Warren Hutchinson
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- EAST FREIGHT SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-12-06
-
SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07872240. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.12.2011 registriert. SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EAST FREIGHT SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.12.2014.Die Firma kann schriftlich über Dsi Business Recovery Ashfield House erreicht werden.
Jetzt sichern SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Skylift Access Hire Limited - Dsi Business Recovery Ashfield House, Illingworth St, Ossett, WF5 8AL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SKYLIFT ACCESS HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-02-26) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-07-27) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-11-26) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-05-30) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-05-30) - 600
-
resolution (2019-05-30) - RESOLUTIONS
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-01) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-13) - GAZ1
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-18) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-14) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-31) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-31) - PSC01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-17) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-07-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-23) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2017-01-13) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-19) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-19) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-12-19) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-25) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-29) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-16) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-02) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-04) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-30) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-07-10) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-28) - AD01
-
change-of-name-notice (2012-06-27) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-12-06) - NEWINC