-
PROPER JOY LIMITED - Benwell House, 15-21 Benwell Road, London, N7 7BL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07869362
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Benwell House
- 15-21 Benwell Road
- London
- N7 7BL
- England Benwell House, 15-21 Benwell Road, London, N7 7BL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LOVELOCK, Pamela Jane
- HOLLAND, Louise Elizabeth Jane
- Prokuristen
- DEWAR, John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2011
- Alter der Firma 2011-12-02 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jamie Trevor Oliver
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- FRESH ONE PRODUCTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-16
- Letzte Einreichung: 2023-12-02
-
PROPER JOY LIMITED Firmenbeschreibung
- PROPER JOY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07869362. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.12.2011 registriert. PROPER JOY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FRESH ONE PRODUCTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Benwell House erreicht werden.
Jetzt sichern PROPER JOY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Proper Joy Limited - Benwell House, 15-21 Benwell Road, London, N7 7BL, Grossbritannien
- 2011-12-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROPER JOY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-02-02) - MR04
-
resolution (2021-02-11) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-08) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-04) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-07-04) - CH03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-25) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-02) - AD01
-
resolution (2017-03-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-08) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-02-24) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-23) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-27) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-02) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-13) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-04) - AR01
-
legacy (2012-10-05) - MG02
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-12-22) - MG01
-
incorporation-company (2011-12-02) - NEWINC
-
legacy (2011-12-13) - MG01