-
BIRNEY HALL PROPERTIES LIMITED - JOANNE ROE, Lugano Building, Melbourne Street, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07858757
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- JOANNE ROE
- Lugano Building
- Melbourne Street
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 2JQ JOANNE ROE, Lugano Building, Melbourne Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 2JQ UK
Management
- Geschäftsführung
- JACKSON, Grahame Robert
- LEVY, Haim Judah Michael
- MUNRO, Scott
- RABINOWITZ, Joseph
- ROBSON, Richard John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Allan Rankin
- -
- -
- Mr Ben Zion Rabinowitz
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-19
- Letzte Einreichung: 2021-01-05
-
BIRNEY HALL PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- BIRNEY HALL PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07858757. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Joanne Roe erreicht werden.
Jetzt sichern BIRNEY HALL PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Birney Hall Properties Limited - JOANNE ROE, Lugano Building, Melbourne Street, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
- 2011-11-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BIRNEY HALL PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-12-06) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-07) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-08) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-08) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-08) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-17) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-12-05) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-10-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-05) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-02-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-03) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-02) - AP01
-
incorporation-company (2011-11-23) - NEWINC
-
legacy (2011-12-21) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2011-12-02) - TM01