-
MOUNT ANVIL (UNION STREET) LIMITED - 25, Farringdon Street, London, EC4A 4AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07846558
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25
- Farringdon Street
- London
- EC4A 4AB 25, Farringdon Street, London, EC4A 4AB UK
Management
- Geschäftsführung
- AGNEW, Alastair Thomas
- ANDERSON, Ewan Thomas
- HURLEY, Darragh Richard Joseph
- Prokuristen
- ANDERSON, Ewan Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.11.2011
- Gelöscht am:
- 2022-02-28
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mount Anvil New Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-26
- Letzte Einreichung: 2019-11-14
-
MOUNT ANVIL (UNION STREET) LIMITED Firmenbeschreibung
- MOUNT ANVIL (UNION STREET) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07846558. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 erreicht werden.
Jetzt sichern MOUNT ANVIL (UNION STREET) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mount Anvil (Union Street) Limited - 25, Farringdon Street, London, EC4A 4AB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MOUNT ANVIL (UNION STREET) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-10-22) - 600
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-13) - AD01
-
resolution (2020-10-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-10-22) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-15) - AA
-
legacy (2019-11-15) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-11-15) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-11-15) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-08-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-10) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-19) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-19) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-17) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-02-10) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-10-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-08) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-06-05) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-22) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2013-03-22) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-22) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-07-31) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-01) - AR01
-
resolution (2012-10-09) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2012-10-09) - MEM/ARTS
-
legacy (2012-10-16) - MG01
-
legacy (2012-10-17) - MG01
-
legacy (2012-10-22) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-14) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-12-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-20) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-12-20) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-20) - AD01