-
SECURE A SHIP LIMITED - South Court Hardwick Business Park, Noral Way, Banbury, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07838708
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- South Court Hardwick Business Park
- Noral Way
- Banbury
- Oxfordshire
- OX16 2AF South Court Hardwick Business Park, Noral Way, Banbury, Oxfordshire, OX16 2AF UK
Management
- Geschäftsführung
- MAGUIRE, Paul Edward
- Prokuristen
- MAGUIRE, Paul Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-08 12 Jahre
- SIC/NACE
- 80100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Claire Maguire
- Mr Paul Edward Maguire
- -
- -
- Mr Paul Edward Maguire
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-01-01
- Letzte Einreichung: 2021-12-18
-
SECURE A SHIP LIMITED Firmenbeschreibung
- SECURE A SHIP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07838708. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "80100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über South Court Hardwick Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern SECURE A SHIP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Secure A Ship Limited - South Court Hardwick Business Park, Noral Way, Banbury, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2011-11-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SECURE A SHIP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
legacy (2019-01-22) - RPCH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-02-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-04) - TM01
-
legacy (2018-12-18) - RP04CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-14) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-08-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-16) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-23) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-01) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-05-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-06) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2016-05-18) - SH06
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-20) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-05) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-09) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2015-12-01) - GAZ1
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-12-09) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-04) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-05-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-11-08) - NEWINC