-
VISION BEYOND AUTISM CIC - Flat 2 102a Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5BB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07837841
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Flat 2 102a Water Lane
- Wilmslow
- Cheshire
- SK9 5BB
- England Flat 2 102a Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5BB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYD, Frances Donna
- KANUMILLI, Julie Margaret
- KANUMILLI, Naresh
- REYNER, Jonathan Mark
- REYNER, Tracie Gail
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.11.2011
- Alter der Firma 2011-11-07 12 Jahre
- SIC/NACE
- 85600
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Tracie Gail Reyner
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-21
- Letzte Einreichung: 2023-11-07
-
VISION BEYOND AUTISM CIC Firmenbeschreibung
- VISION BEYOND AUTISM CIC ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07837841. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.11.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85600" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Flat 2 102A Water Lane erreicht werden.
Jetzt sichern VISION BEYOND AUTISM CIC HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vision Beyond Autism Cic - Flat 2 102a Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5BB, Grossbritannien
- 2011-11-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VISION BEYOND AUTISM CIC aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-24) - AA
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2023-11-10) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2023-11-10) - AD02
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-11) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-11) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-21) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-21) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-12-20) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-05-30) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-07) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-12-20) - PSC09
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-28) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-23) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-03) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-05-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-community-interest-company (2011-11-07) - CICINC