-
GK1 COACHING LIMITED - 71-75 Shelton Stret, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07820199
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 71-75 Shelton Stret
- Covent Garden
- London
- WC2H 9JQ
- England 71-75 Shelton Stret, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COPPEN, Jonathan Lawrence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-24 12 Jahre
- SIC/NACE
- 85510
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Darren Mace
- Mr Jonathan Lawrence Coppen
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-05-31
- Letzte Einreichung: 2021-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-01
- Letzte Einreichung: 2022-03-18
-
GK1 COACHING LIMITED Firmenbeschreibung
- GK1 COACHING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07820199. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85510" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 71-75 Shelton Stret erreicht werden.
Jetzt sichern GK1 COACHING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gk1 Coaching Limited - 71-75 Shelton Stret, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Grossbritannien
- 2011-10-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GK1 COACHING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-10-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-12) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-06) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-06-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-25) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-10-04) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-15) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-01-17) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsary (2014-02-25) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-15) - DISS40
-
change-sail-address-company (2014-03-21) - AD02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-24) - NEWINC