-
AMICURA LIMITED - 238 Station Road, Addlestone, KT15 2PS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07793106
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 238 Station Road
- Addlestone
- KT15 2PS 238 Station Road, Addlestone, KT15 2PS UK
Management
- Geschäftsführung
- ALFLATT, John Neal
- FAREBROTHER, Colin William
- PATEL, Mahesh Shivabhai
- Prokuristen
- ALFLATT, John Neal
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-30 12 Jahre
- SIC/NACE
- 87100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Amicura Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- LARCHWOOD CARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-14
- Letzte Einreichung: 2023-09-30
-
AMICURA LIMITED Firmenbeschreibung
- AMICURA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07793106. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.09.2011 registriert. AMICURA LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LARCHWOOD CARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 238 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern AMICURA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Amicura Limited - 238 Station Road, Addlestone, KT15 2PS, Grossbritannien
- 2011-09-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMICURA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
legacy (2023-12-31) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-01-16) - AA
-
legacy (2023-01-16) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-12-31) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2022
-
legacy (2022-12-23) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-26) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-02-15) - MR01
-
legacy (2022-12-23) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-04) - CS01
-
legacy (2021-11-02) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-11-02) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-11-02) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-11-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-25) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-13) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-16) - AA
-
legacy (2019-12-16) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-12-16) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-12-16) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-08) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-09) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-02-22) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-04) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-18) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
-
resolution (2018-12-18) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-04-17) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-03-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-10) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-12) - AP01
-
resolution (2012-03-22) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2012-03-20) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-03-20) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-10-19) - MG01
-
legacy (2011-10-11) - MG01
-
incorporation-company (2011-09-30) - NEWINC