-
ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED - Station House Station Approach, East Horsley, Leatherhead, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07788834
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Station House Station Approach
- East Horsley
- Leatherhead
- Surrey
- KT24 6QX Station House Station Approach, East Horsley, Leatherhead, Surrey, KT24 6QX UK
Management
- Geschäftsführung
- PANKHANIA, Keval
- PATEL, Mayuri
- SPIRES, Alice
- SQUELCH, Ryan David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-27 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Mayuri Patel
- One Avenue Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- KALEIDOS BUSINESS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-10
- Letzte Einreichung: 2020-04-26
-
ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07788834. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.09.2011 registriert. ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen KALEIDOS BUSINESS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Station House Station Approach erreicht werden.
Jetzt sichern ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: One Avenue Acquisitions Limited - Station House Station Approach, East Horsley, Leatherhead, Surrey, Grossbritannien
- 2011-09-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ONE AVENUE ACQUISITIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-10-06) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-13) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-13) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-19) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-29) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-26) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-21) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-21) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-06) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-26) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-10-26) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-26) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-26) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-27) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-group (2017-10-23) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-17) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-11) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-02-21) - TM01
-
change-of-name-notice (2013-04-04) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2013-04-04) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-05-22) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-09-23) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2013-09-23) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-07) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-25) - TM01
-
change-of-name-notice (2013-12-10) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-10) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-21) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-01-10) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-27) - NEWINC