-
MOMEDIA TV LTD - 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07787673
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 264 Banbury Road
- Oxford
- OX2 7DY 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY UK
Management
- Geschäftsführung
- BERTRAND, Lucas
- EVANS, David Garfield
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.09.2011
- Alter der Firma 2011-09-26 12 Jahre
- SIC/NACE
- 59132
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lucas Bertrand
- Mr Lucas Bertrand
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-07
- Letzte Einreichung: 2019-09-26
-
MOMEDIA TV LTD Firmenbeschreibung
- MOMEDIA TV LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07787673. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.09.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59132" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 264 Banbury Road erreicht werden.
Jetzt sichern MOMEDIA TV LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Momedia Tv Ltd - 264 Banbury Road, Oxford, OX2 7DY, Grossbritannien
- 2011-09-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MOMEDIA TV LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-03-01) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-05-22) - LIQ02
-
resolution (2020-05-22) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-22) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-01) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-10) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-30) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-15) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-10) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-10) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-14) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-11-23) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-11-27) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-11-27) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-11-27) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-02) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-09-03) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-10-18) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-05-29) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2012-05-29) - SH10
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-09-14) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-27) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-05-29) - SH08
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-12-05) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-09) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-08) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-08) - AD01
-
incorporation-company (2011-09-26) - NEWINC