-
AQUA COMMAND LTD - C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor Churchgate House, Churchgate, Bolton, BL1 1HL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07786266
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor Churchgate House
- Churchgate
- Bolton
- BL1 1HL C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor Churchgate House, Churchgate, Bolton, BL1 1HL UK
Management
- Geschäftsführung
- COMFORT, John Jervis
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.09.2011
- Gelöscht am:
- 2021-04-07
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Jervis Comfort
- Mr Phillip John Van Tenac
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- VISIBLE APPS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-30
- Letzte Einreichung: 2017-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-15
- Letzte Einreichung: 2019-04-01
-
AQUA COMMAND LTD Firmenbeschreibung
- AQUA COMMAND LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07786266. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.09.2011 registriert. AQUA COMMAND LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VISIBLE APPS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.09.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4Th Floor Churchgate House erreicht werden.
Jetzt sichern AQUA COMMAND LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Aqua Command Ltd - C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor Churchgate House, Churchgate, Bolton, BL1 1HL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AQUA COMMAND LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-01-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-01-07) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-11-30) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-11-30) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-02) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-09-03) - GAZ1
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-10-21) - LIQ02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-26) - AP01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-10-21) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-22) - AD01
-
resolution (2019-10-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-02) - TM01
-
gazette-notice-compulsary (2014-02-18) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-19) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-22) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-25) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-04-25) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-24) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-07-27) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-20) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-28) - AP03
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-26) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-02-07) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-09-26) - NEWINC