-
SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED - The Chapel, Bridge Street, Driffield, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07747405
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chapel
- Bridge Street
- Driffield
- East Yorkshire
- YO25 6DA The Chapel, Bridge Street, Driffield, East Yorkshire, YO25 6DA UK
Management
- Geschäftsführung
- MARTIN, Nicholas John
- MARTIN, Sandra Heward
- Prokuristen
- MARTIN, Sandra Heward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.08.2011
- Gelöscht am:
- 2024-03-01
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Sandra Heward Martin
- Mr Nicholas John Martin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- HALEPORT INVESTMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
-
SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED Firmenbeschreibung
- SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07747405. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.08.2011 registriert. SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HALEPORT INVESTMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Chapel erreicht werden.
Jetzt sichern SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smart Management By Design Limited - The Chapel, Bridge Street, Driffield, East Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMART MANAGEMENT BY DESIGN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-03-01) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2023
-
resolution (2023-08-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-08-22) - 600
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-12-01) - LIQ14
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-08-22) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-08-22) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-23) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-05) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-03-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-01-10) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-01-10) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-11-23) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2011-11-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-23) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2011-11-18) - CERTNM
-
incorporation-company (2011-08-22) - NEWINC