-
7 BIRKENHEAD AVENUE (FREEHOLD) LIMITED - Garden Flat 1, 7 Birkenhead Avenue, Kingston Upon Thames, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07720118
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Garden Flat 1
- 7 Birkenhead Avenue
- Kingston Upon Thames
- Surrey
- KT2 6RW Garden Flat 1, 7 Birkenhead Avenue, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6RW UK
Management
- Geschäftsführung
- VAN DER MERWE, Brad
- DEMIRCI, Zeynel Abidin, Mt
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-27 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Jason Andrews
- -
- Mt Zeynel Abidin Demirci
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-04-30
- Letzte Einreichung: 2021-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-24
- Letzte Einreichung: 2023-03-10
-
7 BIRKENHEAD AVENUE (FREEHOLD) LIMITED Firmenbeschreibung
- 7 BIRKENHEAD AVENUE (FREEHOLD) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07720118. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Garden Flat 1 erreicht werden.
Jetzt sichern 7 BIRKENHEAD AVENUE (FREEHOLD) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 7 Birkenhead Avenue (Freehold) Limited - Garden Flat 1, 7 Birkenhead Avenue, Kingston Upon Thames, Surrey, Grossbritannien
- 2011-07-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 7 BIRKENHEAD AVENUE (FREEHOLD) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-22) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-22) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-03-23) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-09) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-09) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-15) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-15) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-16) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-08-18) - SH01
-
incorporation-company (2011-07-27) - NEWINC