-
ADAM HTT LIMITED - The Pinnacle, 170 Midsummer Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07718565
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Pinnacle
- 170 Midsummer Boulevard
- Milton Keynes
- Buckinghamshire
- MK9 1BP
- United Kingdom The Pinnacle, 170 Midsummer Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1BP, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- MARTIN, Paul Santo
- WOLTER, Ian Reiner
- YOUNG, Julian John Lindsay
- Prokuristen
- DOLAN, Graham John Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-26 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dynamic Procurement Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MATRIX-SPS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-07-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-09
- Letzte Einreichung: 2020-07-26
-
ADAM HTT LIMITED Firmenbeschreibung
- ADAM HTT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07718565. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.07.2011 registriert. ADAM HTT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MATRIX-SPS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.07.2014.Die Firma kann schriftlich über The Pinnacle erreicht werden.
Jetzt sichern ADAM HTT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Adam Htt Limited - The Pinnacle, 170 Midsummer Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2011-07-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ADAM HTT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-05-24) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-04-14) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-27) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-05-20) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-03) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-16) - MR01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-01-07) - PSC09
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-01-06) - PSC09
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-12) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-08) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-09-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-02) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-26) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-26) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-28) - CS01
-
certificate-change-of-name-company (2016-03-31) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-09-25) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2015-09-25) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-08-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-04) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-05-08) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-11-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-15) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-14) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-01-22) - CH03
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-13) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-01-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-04-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-09-15) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-08-29) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-29) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-17) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-08-17) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2012-08-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-26) - NEWINC