-
ANGORA RETAIL LIMITED - 3rd Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4AE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07716703
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor 37 Frederick Place
- Brighton
- BN1 4AE 3rd Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4AE UK
Management
- Geschäftsführung
- FIELDEN, Paul
- HEWKIN, Keiran Christopher Robert
- BOOST&CO LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-25 12 Jahre
- SIC/NACE
- 31090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Michael Mcvicar
- -
- Lombok Retail Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-04-30
- Letzte Einreichung: 2018-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-19
- Letzte Einreichung: 2019-11-07
-
ANGORA RETAIL LIMITED Firmenbeschreibung
- ANGORA RETAIL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07716703. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "31090" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor 37 Frederick Place erreicht werden.
Jetzt sichern ANGORA RETAIL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Angora Retail Limited - 3rd Floor 37 Frederick Place, Brighton, BN1 4AE, Grossbritannien
- 2011-07-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ANGORA RETAIL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-04-23) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2021-03-22) - AM19
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-21) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2020-04-15) - AM01
-
liquidation-in-administration-proposals (2020-06-01) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2020-06-18) - AM06
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-11-09) - AM10
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-07) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-30) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-07-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-04) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2017-12-04) - AP02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-31) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-12) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-11) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-04-24) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-25) - NEWINC
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-12-28) - SH02
-
resolution (2011-12-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2011-11-01) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-28) - AD01
-
capital-allotment-shares (2011-12-09) - SH01