-
WELLERS AUCTIONS LTD - Auction House, Bedford Road, Guildford, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07711220
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Auction House
- Bedford Road
- Guildford
- Surrey
- GU1 4SJ Auction House, Bedford Road, Guildford, Surrey, GU1 4SJ UK
Management
- Geschäftsführung
- LOFTS, Thomas Duncan
- SYKES, Christopher Francis George
- SNELGAR, Andrew Mark
- SNELGAR, Robert Paul
- STUBBS, Andrew John
- SYKES, Natalie Daniele
- Prokuristen
- BOOKHAM, Sally Pauline
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-20 12 Jahre
- SIC/NACE
- 47190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Glen Snelgar
- Mr Christopher Francis George Sykes
- Mr Thomas Duncan Lofts
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WELLERS FINE ART LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-08
- Letzte Einreichung: 2023-05-25
-
WELLERS AUCTIONS LTD Firmenbeschreibung
- WELLERS AUCTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07711220. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.07.2011 registriert. WELLERS AUCTIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WELLERS FINE ART LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47190" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Auction House erreicht werden.
Jetzt sichern WELLERS AUCTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wellers Auctions Ltd - Auction House, Bedford Road, Guildford, Surrey, Grossbritannien
- 2011-07-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WELLERS AUCTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-15) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-08) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-08) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-05) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-11) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-15) - CS01
-
resolution (2020-08-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-09) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-10-09) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-30) - CH01
-
change-of-name-notice (2020-08-25) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-20) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-07) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-05-07) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-08) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-30) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-07) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-31) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-20) - AR01
-
resolution (2014-08-28) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-04) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-01-30) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-11-05) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-11-05) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-20) - NEWINC