-
PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF - 39a Cross Street, Abergavenny, NP7 5ER, Wales, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07705089
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 39a Cross Street
- Abergavenny
- NP7 5ER
- Wales 39a Cross Street, Abergavenny, NP7 5ER, Wales UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, David Edward Owen
- HOLLAND, Jacqueline Deborah
- KONIECZNY, Anthony Eric Bronislaw
- WAKLEY, Gillian Margaret, Dr
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc
- Gründungsdatum
- 14.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-14 12 Jahre
- SIC/NACE
- 94990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Beckett
- -
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THE WELSH GEORGIAN TRUST
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-28
- Letzte Einreichung: 2021-07-14
-
PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF Firmenbeschreibung
- PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc registrierte Firma mit der Register-Nr. 07705089. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.07.2011 registriert. PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE WELSH GEORGIAN TRUST ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "94990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 39A Cross Street erreicht werden.
Jetzt sichern PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Plas Gunter Mansion Trust Cyf - 39a Cross Street, Abergavenny, NP7 5ER, Wales, Grossbritannien
- 2011-07-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PLAS GUNTER MANSION TRUST CYF aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-08) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-02-01) - PSC08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-05) - AA
-
resolution (2020-03-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-06) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charles-court-order-extend-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-12) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-26) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-26) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-23) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-07-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-08-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-08-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-08-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-08-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-14) - NEWINC