-
LILLIE SQUARE GP LIMITED - Regal House, 14 James Street, London, WC2E 8BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07696132
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Regal House
- 14 James Street
- London
- WC2E 8BU
- United Kingdom Regal House, 14 James Street, London, WC2E 8BU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HAWKSWORTH, Ian David
- HENDERSON, Ian James
- KWOK, Edward
- KWOK, Raymond Ping Luen
- LUI, Ting
- TSANG, Terrence
- Prokuristen
- PAVEY, Ruth Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-06 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Capital & Counties Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SEAGRAVE ROAD GP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-20
- Letzte Einreichung: 2021-07-06
-
LILLIE SQUARE GP LIMITED Firmenbeschreibung
- LILLIE SQUARE GP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07696132. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.07.2011 registriert. LILLIE SQUARE GP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SEAGRAVE ROAD GP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Regal House erreicht werden.
Jetzt sichern LILLIE SQUARE GP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lillie Square Gp Limited - Regal House, 14 James Street, London, WC2E 8BU, Grossbritannien
- 2011-07-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LILLIE SQUARE GP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-19) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-11-15) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-17) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-01-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-03-05) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-02) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-10-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-08-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-14) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-01) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-07-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-06-03) - MR01
-
resolution (2014-05-02) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-06-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-of-name-notice (2013-05-09) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-05-13) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-05-09) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-05-18) - MG02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-09-11) - SH08
-
resolution (2012-09-11) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-09-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2012-09-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-11-15) - MG01
-
capital-allotment-shares (2011-11-01) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-11-24) - AA01
-
memorandum-articles (2011-11-15) - MEM/ARTS
-
resolution (2011-11-15) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2011-07-06) - NEWINC