-
CONEXUS MEDSTAFF LIMITED - Suite 29,, West Lancashire Investment Centre, White Moss Business Park, Skelmersdale, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07691722
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 29,
- West Lancashire Investment Centre
- White Moss Business Park
- Skelmersdale
- Lancashire
- WN8 9TG
- United Kingdom Suite 29,, West Lancashire Investment Centre, White Moss Business Park, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9TG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DOCWRA, Kirsty
- MORETON, Andrew James
- MORETON, Brian David
- MORETON, Carol Evelyn
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-04 12 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brian David Moreton
- Mrs Carol Evelyn Moreton
- Mr Andrew James Moreton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LINK HOSPITAL & HEALTHCARE PROFESSIONALS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 549300XGSWKGZSETO823
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-18
- Letzte Einreichung: 2019-07-04
-
CONEXUS MEDSTAFF LIMITED Firmenbeschreibung
- CONEXUS MEDSTAFF LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07691722. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.07.2011 registriert. CONEXUS MEDSTAFF LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LINK HOSPITAL & HEALTHCARE PROFESSIONALS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.07.2013.Die Firma kann schriftlich über Suite 29 erreicht werden.
Jetzt sichern CONEXUS MEDSTAFF LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Conexus Medstaff Limited - Suite 29,, West Lancashire Investment Centre, White Moss Business Park, Skelmersdale, Grossbritannien
- 2011-07-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONEXUS MEDSTAFF LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-06-10) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-05-11) - SH02
-
resolution (2020-05-19) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-05-18) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-13) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-08) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-08) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-08) - AA
-
resolution (2016-09-29) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-19) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-04-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-08) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-16) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-19) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-24) - AR01
-
legacy (2012-11-28) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-14) - AP01
-
change-of-name-notice (2011-07-18) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2011-07-18) - CERTNM
-
resolution (2011-07-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-07-19) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-19) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-07-19) - TM02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-07-19) - AA01
-
incorporation-company (2011-07-04) - NEWINC