-
RMA EVENTS LTD - Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07689602
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D, Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- STEEL, Angus Kennedy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.07.2011
- Gelöscht am:
- 2021-09-17
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Angus Kennedy Steel
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HEGSTRORDINARY MANAGEMENT LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-04-30
- Letzte Einreichung: 2016-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-13
- Letzte Einreichung: 2019-07-02
-
RMA EVENTS LTD Firmenbeschreibung
- RMA EVENTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07689602. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.07.2011 registriert. RMA EVENTS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HEGSTRORDINARY MANAGEMENT LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Office D, Beresford House erreicht werden.
Jetzt sichern RMA EVENTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rma Events Ltd - Office D, Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RMA EVENTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-09-17) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-06-17) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-24) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-12-24) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2020-11-12) - CVA4
-
resolution (2020-12-30) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-08) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-30) - AD01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-11-02) - CVA3
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2018-12-12) - CVA1
-
liquidation-in-administration-end-of-administration (2018-10-15) - AM21
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-05-29) - AM07
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-05-09) - AM03
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-04-17) - AM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-16) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-03-14) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-02-02) - MR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-08) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-06) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-05) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-09) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-07) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-10-28) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-08-05) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-10-14) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-14) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-08-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-15) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-17) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2012-02-17) - CONNOT
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-12-30) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2011-12-30) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-03) - AD01
-
incorporation-company (2011-07-01) - NEWINC