-
BLUE SQUARE ASSETS (CLEOBURY MORTIMER) LIMITED - Harpal House 14 Holyhead Road, Handsworth, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07687630
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Harpal House 14 Holyhead Road
- Handsworth
- Birmingham
- West Midlands
- B21 0LT
- England Harpal House 14 Holyhead Road, Handsworth, Birmingham, West Midlands, B21 0LT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-29 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Rajesh Sodhi
- Mr Rajesh Sodhi
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-16
- Letzte Einreichung: 2021-10-02
-
BLUE SQUARE ASSETS (CLEOBURY MORTIMER) LIMITED Firmenbeschreibung
- BLUE SQUARE ASSETS (CLEOBURY MORTIMER) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07687630. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Harpal House 14 Holyhead Road erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE SQUARE ASSETS (CLEOBURY MORTIMER) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue Square Assets (Cleobury Mortimer) Limited - Harpal House 14 Holyhead Road, Handsworth, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
- 2011-06-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE SQUARE ASSETS (CLEOBURY MORTIMER) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-19) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-20) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-19) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-24) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-27) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-11) - AR01
-
legacy (2013-02-22) - MG02
-
termination-director-company-with-name (2013-01-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-01) - MG01
-
legacy (2012-03-02) - MG01
-
legacy (2012-04-02) - MG02
-
legacy (2012-04-04) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-12) - TM01
-
legacy (2012-10-01) - MG01
-
capital-allotment-shares (2012-10-03) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-03) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-05) - AP01
-
legacy (2012-10-13) - MG01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-15) - TM01
-
legacy (2012-10-19) - MG02
-
legacy (2012-10-20) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-11-30) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-23) - AP01
-
incorporation-company (2011-06-29) - NEWINC