-
STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED - 3rd Floor The Pinnacle, 73 King Street, Manchester, M2 4NG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07680662
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor The Pinnacle
- 73 King Street
- Manchester
- M2 4NG 3rd Floor The Pinnacle, 73 King Street, Manchester, M2 4NG UK
Management
- Geschäftsführung
- BOMBERG, Iain Alexander
- WILKINSON, Jonathan Richard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-23 12 Jahre
- SIC/NACE
- 38110
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- HALLP HAJCO 028 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-07-07
- Letzte Einreichung:
-
STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED Firmenbeschreibung
- STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07680662. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2011 registriert. STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HALLP HAJCO 028 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor The Pinnacle erreicht werden.
Jetzt sichern STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stamford Renewable Fuels Limited - 3rd Floor The Pinnacle, 73 King Street, Manchester, M2 4NG, Grossbritannien
- 2011-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STAMFORD RENEWABLE FUELS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-02-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-02-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-02-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-02-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-01-26) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-31) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-12-21) - 600
-
liquidation-disclaimer-notice (2015-12-23) - F10.2
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-12-21) - 4.20
-
resolution (2015-12-21) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2015-06-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-17) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2014-06-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
-
legacy (2013-02-04) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-16) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-01-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-17) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-16) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-16) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-11-16) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-16) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2011-10-28) - CERTNM
-
incorporation-company (2011-06-23) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2011-10-28) - CONNOT