-
THE TRAILERFARM LIMITED - 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07670603
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 201 Temple Chambers
- 3-7 Temple Avenue
- London
- EC4Y 0DT
- United Kingdom 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DURANTI, Giacomo
- PORTER, Daniel
- PORTER, Tony
- SIOLI, Fulvio
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-15 12 Jahre
- SIC/NACE
- 58290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Daniel Porter
- -
- Mr Tony Porter
- Keywords Uk Holdings Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-09-26
- Letzte Einreichung: 2018-09-12
-
THE TRAILERFARM LIMITED Firmenbeschreibung
- THE TRAILERFARM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07670603. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 201 Temple Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern THE TRAILERFARM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Trailerfarm Limited - 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, Grossbritannien
- 2011-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE TRAILERFARM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-01) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-31) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-01-31) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-01) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-01) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-13) - MR04
-
resolution (2018-09-21) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-01) - AA
-
memorandum-articles (2018-09-21) - MA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-01) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-27) - AA
-
resolution (2017-02-14) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-02-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-10-09) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-30) - AP01
-
resolution (2016-09-21) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-02) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-09-30) - SH08
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-14) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-17) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsary (2014-07-01) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-09) - DISS40
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-03-07) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-06) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-05-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-02) - AD01
-
incorporation-company (2011-06-15) - NEWINC