-
GENERATE LAND LIMITED - Central House Otley Road, Beckwith Knowle, Harrogate, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07664466
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Central House Otley Road
- Beckwith Knowle
- Harrogate
- North Yorkshire
- HG3 1UF
- England Central House Otley Road, Beckwith Knowle, Harrogate, North Yorkshire, HG3 1UF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROOKS, Anthony
- BROOKS, Daniel Reuben
- BROOKS, Oscar Anthony
- PARKER, Andrew Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-10 12 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Daniel Reuben Brooks
- Mrs Alison Jane Brooks
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-25
- Letzte Einreichung: 2023-08-11
-
GENERATE LAND LIMITED Firmenbeschreibung
- GENERATE LAND LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07664466. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Central House Otley Road erreicht werden.
Jetzt sichern GENERATE LAND LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Generate Land Limited - Central House Otley Road, Beckwith Knowle, Harrogate, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2011-06-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GENERATE LAND LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
capital-allotment-shares (2023-07-12) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2023-07-18) - RP04SH01
-
capital-allotment-shares (2023-08-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-08-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-02-20) - PSC07
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-31) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-10-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-02) - AA
-
capital-allotment-shares (2021-08-17) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-29) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-27) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-12) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-07-31) - SH08
-
resolution (2015-07-31) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-27) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-27) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-02) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-27) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-08-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-07-10) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-04-09) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-10) - NEWINC