-
JEENISON SERVICES LIMITED - Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, SK4 2LP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07655812
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Minshull House
- 67 Wellington Road North
- Stockport
- SK4 2LP Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, SK4 2LP UK
Management
- Geschäftsführung
- RACOMBO, Raphael Maxwell
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-02 12 Jahre
- SIC/NACE
- 46900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Anatoliy Vyal
- Mr. Anatoliy Vyal
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-01
- Letzte Einreichung: 2022-08-18
-
JEENISON SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- JEENISON SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07655812. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Minshull House erreicht werden.
Jetzt sichern JEENISON SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jeenison Services Limited - Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, SK4 2LP, Grossbritannien
- 2011-06-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JEENISON SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-09) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-06-15) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-09-07) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2022-09-13) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-26) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-26) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-09-27) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2021-07-26) - AD03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-26) - CS01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2021-07-28) - AD02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-15) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-13) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-06-04) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-06) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
elect-to-keep-the-persons-with-significant-control-register-information-on-the-public-register (2017-06-19) - EH04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-08-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-07) - AP01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2015-06-25) - AD02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-07) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-13) - AD01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2015-06-26) - AD03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-02-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-06-02) - NEWINC