-
CORNER FLAG LIMITED - Crown And Anchor 222 Fore Street, Edmonton, London, N18 2QD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07653000
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Crown And Anchor 222 Fore Street
- Edmonton
- London
- N18 2QD Crown And Anchor 222 Fore Street, Edmonton, London, N18 2QD UK
Management
- Geschäftsführung
- DEVLIN, Louise
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-31 13 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-02-28
- Letzte Einreichung: 2015-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-06-14
- Letzte Einreichung:
-
CORNER FLAG LIMITED Firmenbeschreibung
- CORNER FLAG LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07653000. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Crown And Anchor 222 Fore Street erreicht werden.
Jetzt sichern CORNER FLAG LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Corner Flag Limited - Crown And Anchor 222 Fore Street, Edmonton, London, N18 2QD, Grossbritannien
- 2011-05-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CORNER FLAG LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2020-01-30) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-15) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-06-09) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-18) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-21) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-17) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-01-12) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-06-21) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-15) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-05-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-31) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-11) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-06-24) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-23) - AD01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-06-10) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2015-06-02) - GAZ1
-
gazette-notice-compulsory (2015-12-29) - GAZ1
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-01-26) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-06) - TM01
-
gazette-notice-compulsary (2014-09-30) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-06-21) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-18) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-06-14) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-06-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-10-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-03-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-03-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-02) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-10-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-09-24) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-09-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-05-31) - NEWINC