-
RCS LONDON PROCUREMENT LTD - 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07648929
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor 21 Station Road
- Watford
- Herts
- WD17 1AP 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP UK
Management
- Geschäftsführung
- RAYAREL, Ravi
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-26 13 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ravi Rayarel
- Mr Ravi Rayarel
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-02-29
- Letzte Einreichung: 2018-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-15
- Letzte Einreichung: 2019-12-04
-
RCS LONDON PROCUREMENT LTD Firmenbeschreibung
- RCS LONDON PROCUREMENT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07648929. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor 21 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern RCS LONDON PROCUREMENT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rcs London Procurement Ltd - 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP, Grossbritannien
- 2011-05-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RCS LONDON PROCUREMENT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-12) - AD01
-
resolution (2020-06-11) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-06-11) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-08-20) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-04-03) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-31) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-28) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-23) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-05-22) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-05-02) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-04) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-15) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-18) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-19) - DISS40
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-05-23) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-06-14) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-12) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2014-06-03) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-24) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-05-29) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-05-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-27) - AD01
-
incorporation-company (2011-05-26) - NEWINC