-
VIRTUS TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS LTD - Azets, Ventura Park Road, Tamworth, B78 3HL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07644316
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Azets
- Ventura Park Road
- Tamworth
- B78 3HL
- England Azets, Ventura Park Road, Tamworth, B78 3HL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LOWE, Darren Keith
- SEARS, Neil Brian
- SPREADBURY, Paul Dominic
- Prokuristen
- SEARS, Sarah Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 52290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Neil Brian Sears
- Mr Darren Keith Lowe
- Mr Paul Dominic Spreadbury
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2021-05-17
-
VIRTUS TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- VIRTUS TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07644316. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52290" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Azets erreicht werden.
Jetzt sichern VIRTUS TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Virtus Traffic Management Solutions Ltd - Azets, Ventura Park Road, Tamworth, B78 3HL, Grossbritannien
- 2011-05-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIRTUS TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-02) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-08-02) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-08-02) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-02) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-08-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-04) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-06-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-20) - AA
-
capital-allotment-shares (2020-06-01) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-17) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-17) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-02) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-31) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-03-01) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-20) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-13) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-06-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-23) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-12-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-06-29) - AP03
-
incorporation-company (2011-05-23) - NEWINC