-
CEP BIOMASS LIMITED - 4th Floor The Peak, 5 Wilton Road, London, SW1V 1AN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07640793
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor The Peak
- 5 Wilton Road
- London
- SW1V 1AN
- England 4th Floor The Peak, 5 Wilton Road, London, SW1V 1AN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PATEL, Minal
- UNWIN, Hugh Alexander
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-19 13 Jahre
- SIC/NACE
- 64202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Greencoat Ceres Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-30
- Letzte Einreichung: 2021-11-16
-
CEP BIOMASS LIMITED Firmenbeschreibung
- CEP BIOMASS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07640793. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor The Peak erreicht werden.
Jetzt sichern CEP BIOMASS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cep Biomass Limited - 4th Floor The Peak, 5 Wilton Road, London, SW1V 1AN, Grossbritannien
- 2011-05-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CEP BIOMASS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-29) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-12) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-09-16) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-28) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-05-28) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-28) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-28) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-05-28) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-28) - AP01
-
resolution (2020-06-18) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-06-18) - MA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-08-10) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-29) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-06-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-07-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-02-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-06-08) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-12-12) - MG01
-
legacy (2011-10-20) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-14) - AP01
-
incorporation-company (2011-05-19) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-06) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-11-01) - AA01