-
ST. IVES CHAMBERS LIMITED - Whittall Street, Birmingham, West Midlands, B4 6DH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07631331
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Whittall Street
- Birmingham
- West Midlands
- B4 6DH Whittall Street, Birmingham, West Midlands, B4 6DH UK
Management
- Geschäftsführung
- ROGERS, Gregory
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-12 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Joseph Keehan
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-05-26
- Letzte Einreichung: 2022-05-12
-
ST. IVES CHAMBERS LIMITED Firmenbeschreibung
- ST. IVES CHAMBERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07631331. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69101" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.05.2012.Die Firma kann schriftlich über Whittall Street erreicht werden.
Jetzt sichern ST. IVES CHAMBERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St. Ives Chambers Limited - Whittall Street, Birmingham, West Midlands, B4 6DH, Grossbritannien
- 2011-05-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST. IVES CHAMBERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-04-20) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-05-17) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-05-17) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-05-19) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2022-05-26) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2022-06-07) - GAZ1(A)
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2022-06-08) - DS02
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-31) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-05-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-21) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-23) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-23) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-31) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-05-12) - AA01
-
incorporation-company (2011-05-12) - NEWINC