-
FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD - Simarco House, Crittall Road, Witham, CM8 3DR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07626463
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Simarco House
- Crittall Road
- Witham
- CM8 3DR
- England Simarco House, Crittall Road, Witham, CM8 3DR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KNOWLES, David
- SCOTT, Trevor
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 52103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Simarco International Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-05-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-23
- Letzte Einreichung: 2024-05-09
-
FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD Firmenbeschreibung
- FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07626463. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52103" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.05.2014.Die Firma kann schriftlich über Simarco House erreicht werden.
Jetzt sichern FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Formula Goss International Ltd - Simarco House, Crittall Road, Witham, CM8 3DR, Grossbritannien
- 2011-05-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FORMULA GOSS INTERNATIONAL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-04-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-06) - AA
-
legacy (2018-05-24) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-15) - CS01
-
legacy (2018-05-11) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-04-13) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-20) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-20) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-25) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-20) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-26) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-20) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-18) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-11) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-11-11) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-05-09) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-10-04) - AA01