-
MYRTLE FARM LIMITED - 9a Oakhill Road, Shenley Church End, Milton Keynes, MK5 6AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07618639
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9a Oakhill Road
- Shenley Church End
- Milton Keynes
- MK5 6AR 9a Oakhill Road, Shenley Church End, Milton Keynes, MK5 6AR UK
Management
- Geschäftsführung
- BRIDGER, David Paul
- BRIDGER, John Denis
- NEWMAN, Anne Teresa
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.05.2011
- Alter der Firma 2011-05-03 13 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Anne Theresa Newman
- Mr David Paul Bridger
- Mr John Denis Bridger
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-05
- Letzte Einreichung: 2023-04-05
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-17
- Letzte Einreichung: 2023-05-03
-
MYRTLE FARM LIMITED Firmenbeschreibung
- MYRTLE FARM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07618639. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.05.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 9A Oakhill Road erreicht werden.
Jetzt sichern MYRTLE FARM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Myrtle Farm Limited - 9a Oakhill Road, Shenley Church End, Milton Keynes, MK5 6AR, Grossbritannien
- 2011-05-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MYRTLE FARM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-12-07) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-dormant (2021-10-28) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-02) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-17) - MR04
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-05) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-01) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-05-31) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-05-31) - AD01
-
legacy (2012-01-17) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-05-17) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-05-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-16) - AP01
-
incorporation-company (2011-05-03) - NEWINC