-
YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD - C/O, KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED, 1 City Road East, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07576072
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O
- KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED
- 1 City Road East
- Manchester
- M15 4PN C/O, KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED, 1 City Road East, Manchester, M15 4PN UK
Management
- Geschäftsführung
- YOUNG, Nicholas Sylvester Stephen
- Prokuristen
- YOUNG, Lindsey Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2011
- Gelöscht am:
- 2020-09-01
- SIC/NACE
- 43210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Sylvester Stephen Young
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- COTSWOLD ENERGY SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-12-31
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-23
-
YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD Firmenbeschreibung
- YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07576072. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.03.2011 registriert. YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COTSWOLD ENERGY SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.03.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o erreicht werden.
Jetzt sichern YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Young Electrical & Renewables Ltd - C/O, KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED, 1 City Road East, Manchester, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu YOUNG ELECTRICAL & RENEWABLES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-09-01) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-02) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-06-01) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-27) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-11-22) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-11-22) - 600
-
resolution (2017-11-22) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-06-02) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-02) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-01) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-20) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-07) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-05) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-02-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-02-03) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-13) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-02-15) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-30) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-03-30) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-03-28) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-03-28) - TM01
-
incorporation-company (2011-03-23) - NEWINC