-
BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED - 14, Ennis Square, Dormanstown, Redcar, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07575609
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14
- Ennis Square
- Dormanstown
- Redcar
- TS10 5JR 14, Ennis Square, Dormanstown, Redcar, TS10 5JR UK
Management
- Geschäftsführung
- DU ROSE, Rosemary
- GAMBLES, Andrew Frederick Charles
- HANLON, Kevin
- HAYWARD, James Douglas
- Prokuristen
- PEACOCK, Lyn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 55900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- COAST & COUNTRY DEVELOPMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-06
- Letzte Einreichung: 2020-03-23
-
BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07575609. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.03.2011 registriert. BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COAST & COUNTRY DEVELOPMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55900" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 14 erreicht werden.
Jetzt sichern BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Beyond Housing Developments Limited - 14, Ennis Square, Dormanstown, Redcar, Grossbritannien
- 2011-03-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BEYOND HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
certificate-change-of-name-company (2020-10-08) - CERTNM
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
auditors-resignation-company (2019-11-13) - AUD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-01-03) - PSC08
-
resolution (2018-12-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-05) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-07) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-12-19) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-07-09) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-22) - TM01
-
resolution (2015-04-01) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-11-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-10) - AP01
-
incorporation-company (2011-03-23) - NEWINC