-
SUNNY INTERVALS LIMITED - Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, County Durham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07564686
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bede House
- 3 Belmont Business Park
- Durham
- County Durham
- DH1 1TW Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, County Durham, DH1 1TW UK
Management
- Geschäftsführung
- STANIFORTH, Aisla Janie
- STANIFORTH, James Rupert Piers
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Aisla Jane Staniforth
- Mr James Rupert Piers Staniforth
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-26
- Letzte Einreichung: 2020-03-15
-
SUNNY INTERVALS LIMITED Firmenbeschreibung
- SUNNY INTERVALS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07564686. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.03.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Bede House erreicht werden.
Jetzt sichern SUNNY INTERVALS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sunny Intervals Limited - Bede House, 3 Belmont Business Park, Durham, County Durham, Grossbritannien
- 2011-03-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SUNNY INTERVALS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2024-01-03) - LIQ06
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-09-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-09-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-01-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-07) - 600
-
resolution (2020-09-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-12) - CS01
-
resolution (2017-02-14) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-02-11) - SH08
-
capital-allotment-shares (2017-02-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-31) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2014-07-15) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-10-11) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-20) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-08-04) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-01) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-07-27) - SH01
-
gazette-notice-compulsary (2012-07-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-03-21) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-21) - AP01
-
incorporation-company (2011-03-15) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2011-03-21) - TM01