-
LONDON FILM MUSEUM (COVENT GARDEN) LIMITED - Warner House, 98 Theobalds Road, London, WC1X 8WB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07540740
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Warner House
- 98 Theobalds Road
- London
- WC1X 8WB
- England Warner House, 98 Theobalds Road, London, WC1X 8WB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BISONI, David
- ROOTS, Sarah Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 91020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Jonathan Sands
- Eric Senat
- Paul Mendoza
- Warner Bros. Studios Leavesden Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-11-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-29
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-09
- Letzte Einreichung: 2020-06-25
-
LONDON FILM MUSEUM (COVENT GARDEN) LIMITED Firmenbeschreibung
- LONDON FILM MUSEUM (COVENT GARDEN) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07540740. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "91020" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Warner House erreicht werden.
Jetzt sichern LONDON FILM MUSEUM (COVENT GARDEN) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: London Film Museum (Covent Garden) Limited - Warner House, 98 Theobalds Road, London, WC1X 8WB, Grossbritannien
- 2011-02-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LONDON FILM MUSEUM (COVENT GARDEN) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-03-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-26) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2020-08-11) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-01-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-26) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-25) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-02-08) - AA01
-
resolution (2019-01-02) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-05) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-15) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-11-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-17) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-17) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-17) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-19) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-17) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-10-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-25) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-10-28) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-16) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-22) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-10-30) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-11-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-04-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-02) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-25) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-25) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-23) - TM01
-
incorporation-company (2011-02-23) - NEWINC