-
FLOW METERING COMPANY LIMITED - 8 Hopper Way, Diss, Norfolk, IP22 4GT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07539932
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Hopper Way
- Diss
- Norfolk
- IP22 4GT
- England 8 Hopper Way, Diss, Norfolk, IP22 4GT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MONACO, Alessandro
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 09100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mirabello Srl
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-08
- Letzte Einreichung: 2023-02-23
-
FLOW METERING COMPANY LIMITED Firmenbeschreibung
- FLOW METERING COMPANY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07539932. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "09100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.02.2015.Die Firma kann schriftlich über 8 Hopper Way erreicht werden.
Jetzt sichern FLOW METERING COMPANY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Flow Metering Company Limited - 8 Hopper Way, Diss, Norfolk, IP22 4GT, Grossbritannien
- 2011-02-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FLOW METERING COMPANY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-voluntary (2023-05-23) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2023-06-23) - SOAS(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-17) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-05-15) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-09) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-28) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-24) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-03) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-05-28) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date (2015-02-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2014-03-03) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-20) - AA
-
legacy (2013-03-28) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-27) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-09-20) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-02-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-02-24) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-12-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-15) - AP01
-
incorporation-company (2011-02-23) - NEWINC