-
SOUTH WEST FABRICATIONS LTD - 69 High Street, Bideford, Devon, EX39 2AT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07524399
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 69 High Street
- Bideford
- Devon
- EX39 2AT 69 High Street, Bideford, Devon, EX39 2AT UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-10 13 Jahre
- SIC/NACE
- 25620
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Anthony Brent
- Mr Neil Frederick Brent
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BRENT LEASING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-24
- Letzte Einreichung: 2021-02-10
-
SOUTH WEST FABRICATIONS LTD Firmenbeschreibung
- SOUTH WEST FABRICATIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07524399. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.02.2011 registriert. SOUTH WEST FABRICATIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BRENT LEASING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25620" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 69 High Street erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH WEST FABRICATIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South West Fabrications Ltd - 69 High Street, Bideford, Devon, EX39 2AT, Grossbritannien
- 2011-02-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH WEST FABRICATIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-04-06) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-05-20) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-11-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-15) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-02-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-12-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-21) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-04-19) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-of-name-notice (2012-01-11) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-28) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-02-08) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-08) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-11) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-02-18) - SH01
-
incorporation-company (2011-02-10) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2011-02-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-18) - AP01