-
M2 PAISLEY LIMITED - Condor House, St Paul's Churchyard, London, EC4M 8AL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07521907
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Condor House
- St Paul's Churchyard
- London
- EC4M 8AL
- United Kingdom Condor House, St Paul's Churchyard, London, EC4M 8AL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- KING, Allan Alexander
- KING, Allan Duncan
- MILLOY, David Thomas
- YOUNG, Eric Macfie
- Prokuristen
- PARK, Katherine Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-08 13 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- M2 Ventures Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MILLER DEVELOPMENTS FIVE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-16
- Letzte Einreichung: 2020-02-02
-
M2 PAISLEY LIMITED Firmenbeschreibung
- M2 PAISLEY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07521907. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.02.2011 registriert. M2 PAISLEY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MILLER DEVELOPMENTS FIVE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Condor House erreicht werden.
Jetzt sichern M2 PAISLEY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: M2 Paisley Limited - Condor House, St Paul's Churchyard, London, EC4M 8AL, Grossbritannien
- 2011-02-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu M2 PAISLEY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-09-11) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-03) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-23) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-26) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-26) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-04) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-08-21) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-06-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-09) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-09) - PSC07
-
resolution (2018-08-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-03) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-08) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-11-17) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-06-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-18) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-06-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-31) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-31) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-08-12) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-22) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-02-17) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-14) - AP01
-
incorporation-company (2011-02-08) - NEWINC