-
PERCIVAL MEDIA LIMITED - 3rd Floor 114a Cromwell Road, London, SW7 4AG, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07503948
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor 114a Cromwell Road
- London
- SW7 4AG
- United Kingdom 3rd Floor 114a Cromwell Road, London, SW7 4AG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DREWRY, Thomas Laurent Jolyon
- Prokuristen
- DREWRY, Thomas Laurent Jolyon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.01.2011
- Gelöscht am:
- 2021-12-07
- SIC/NACE
- 58110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Thomas Laurent Jolyon Drewry
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- BLUFFER'S MEDIA LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-24
-
PERCIVAL MEDIA LIMITED Firmenbeschreibung
- PERCIVAL MEDIA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07503948. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 24.01.2011 registriert. PERCIVAL MEDIA LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BLUFFER'S MEDIA LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor 114A Cromwell Road erreicht werden.
Jetzt sichern PERCIVAL MEDIA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Percival Media Limited - 3rd Floor 114a Cromwell Road, London, SW7 4AG, United Kingdom, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PERCIVAL MEDIA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-12-07) - GAZ2(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-02) - CS01
-
resolution (2021-04-21) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-04-21) - CAP-SS
-
gazette-notice-voluntary (2021-09-21) - GAZ1(A)
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-05-13) - SH19
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-09-10) - DS01
-
legacy (2021-04-21) - SH20
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-02) - AA
-
resolution (2018-04-26) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-12) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-25) - AR01
-
resolution (2015-02-24) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-02-20) - SH02
-
second-filing-of-form-with-form-type (2015-02-19) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-18) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-01-27) - SH01
-
resolution (2015-01-14) - RESOLUTIONS
-
legacy (2015-01-14) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-01-14) - SH19
-
legacy (2015-01-14) - CAP-SS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-04) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-13) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-06-13) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-02-21) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-02-21) - CH03
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-03) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-03-25) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-02-24) - AA01
-
incorporation-company (2011-01-24) - NEWINC