-
DONT DELIVER LATE LTD - B6 Safestore Elstow Road, Kempston, Bedford, MK42 8PL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07499650
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- B6 Safestore Elstow Road
- Kempston
- Bedford
- MK42 8PL
- England B6 Safestore Elstow Road, Kempston, Bedford, MK42 8PL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HILL, Joanne
- MILES, Grant
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Karl Hill
- Mr Karl Hill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-30
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-17
- Letzte Einreichung: 2023-01-03
-
DONT DELIVER LATE LTD Firmenbeschreibung
- DONT DELIVER LATE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07499650. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über B6 Safestore Elstow Road erreicht werden.
Jetzt sichern DONT DELIVER LATE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dont Deliver Late Ltd - B6 Safestore Elstow Road, Kempston, Bedford, MK42 8PL, Grossbritannien
- 2011-01-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DONT DELIVER LATE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-15) - AA
-
capital-allotment-shares (2022-03-11) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-30) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-08-31) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-09-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-16) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-12-16) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-16) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-08-30) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-20) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-16) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-30) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-01-30) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-30) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-29) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-01) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-05-03) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-10-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-04-02) - MG01
-
incorporation-company (2011-01-20) - NEWINC