-
WHEATON EUROPE LIMITED - 15 Canada Square, London, E14 5GL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07497958
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Canada Square
- London
- E14 5GL 15 Canada Square, London, E14 5GL UK
Management
- Geschäftsführung
- RELCHE, Armin Heinz
- ROWLANDS, Gareth
- WARD, Michaela
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-19 13 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Wheaton Industries Inc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-02
- Letzte Einreichung: 2021-01-19
-
WHEATON EUROPE LIMITED Firmenbeschreibung
- WHEATON EUROPE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07497958. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 15 Canada Square erreicht werden.
Jetzt sichern WHEATON EUROPE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wheaton Europe Limited - 15 Canada Square, London, E14 5GL, Grossbritannien
- 2011-01-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHEATON EUROPE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-06) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2021-08-06) - LIQ06
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-06) - 600
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-06-16) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-06-16) - LIQ01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-03) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-06-16) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-04-07) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-23) - AP01
-
resolution (2016-11-29) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-07) - MR01
-
resolution (2016-11-15) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-11-29) - MA
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-09) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-03-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-07) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-05-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-08-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-05-22) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-group (2012-10-01) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-07-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
capital-allotment-shares (2011-02-15) - SH01
-
resolution (2011-02-15) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2011-01-19) - NEWINC