-
KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED - 4 St Dunstans Technology Park, Ripley Street, Bradford, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07487163
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 St Dunstans Technology Park
- Ripley Street
- Bradford
- West Yorkshire
- BD4 7HH 4 St Dunstans Technology Park, Ripley Street, Bradford, West Yorkshire, BD4 7HH UK
Management
- Geschäftsführung
- FISHER, Robin Charles
- ZEIDLER, Geoffrey Peter Louis
- Prokuristen
- KEHOE, Gaynor Amanda
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-10 13 Jahre
- SIC/NACE
- 85320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Kings Solutions Group Limited
- Kings Solutions Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CLOUD KINGS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-30
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-03
- Letzte Einreichung: 2021-07-20
-
KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED Firmenbeschreibung
- KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07487163. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.01.2011 registriert. KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CLOUD KINGS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 4 St Dunstans Technology Park erreicht werden.
Jetzt sichern KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kings Training Academy Limited - 4 St Dunstans Technology Park, Ripley Street, Bradford, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2011-01-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KINGS TRAINING ACADEMY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-08-08) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-13) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-29) - GAZ1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-12) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-20) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-08-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-31) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-08-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-of-name-notice (2016-05-13) - CONNOT
-
change-of-name-request-comments (2016-05-13) - NM06
-
resolution (2016-05-13) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-11-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-06) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-10) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-07-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-15) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-02-21) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-04-24) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-09-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-31) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-07-19) - MG01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-04-23) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-04-23) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-01-10) - NEWINC