-
LONDON DOORS RESTAURANT GROUP LIMITED - Hayes House, 6 Hayes Road, Bromley, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07486988
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hayes House
- 6 Hayes Road
- Bromley
- Kent
- BR2 9AA Hayes House, 6 Hayes Road, Bromley, Kent, BR2 9AA UK
Management
- Geschäftsführung
- UMUR, Eryiğit
- YEGIN, Nimet Yazoglu
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.01.2011
- Gelöscht am:
- 2021-03-09
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Nahita Restoran Isletmeciligi Ve Yatirim A.S
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-04
- Letzte Einreichung: 2019-03-21
-
LONDON DOORS RESTAURANT GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- LONDON DOORS RESTAURANT GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07486988. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hayes House erreicht werden.
Jetzt sichern LONDON DOORS RESTAURANT GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: London Doors Restaurant Group Limited - Hayes House, 6 Hayes Road, Bromley, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LONDON DOORS RESTAURANT GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-03) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-02-25) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-25) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-02) - 600
-
resolution (2020-03-02) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-03-02) - LIQ02
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-09) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-25) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-27) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-12-19) - DISS16(SOAS)
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-27) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-09-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-30) - TM01
-
resolution (2018-07-19) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-21) - CS01
-
memorandum-articles (2018-09-05) - MA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-19) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-16) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-05-27) - AA
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-04-05) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-04-06) - AD03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-12-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-29) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-12-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-02-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-09-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-18) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-04) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-03-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-12-06) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-08) - AP01
-
incorporation-company (2011-01-10) - NEWINC