-
UTILITY SERVICE SOLUTIONS LIMITED - 89 Leigh Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 9DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07477156
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 89 Leigh Road
- Eastleigh
- Hampshire
- SO50 9DQ 89 Leigh Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 9DQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BRODERICK, Marianne Elaine
- EVANS, Elaine Anne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-06
- Letzte Einreichung: 2019-12-23
-
UTILITY SERVICE SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- UTILITY SERVICE SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07477156. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 89 Leigh Road erreicht werden.
Jetzt sichern UTILITY SERVICE SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Utility Service Solutions Limited - 89 Leigh Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 9DQ, Grossbritannien
- 2010-12-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UTILITY SERVICE SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-09) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-12-12) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-12) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2018-12-12) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-03-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-23) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-01-20) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-02-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-23) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-01-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-04-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-23) - NEWINC