-
ELLOUGH AD PLANT LIMITED - 4th Floor 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07475331
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor 36 Spital Square
- London
- E1 6DY 4th Floor 36 Spital Square, London, E1 6DY UK
Management
- Geschäftsführung
- BULLEN, Dean Peter
- WATERS, Christopher Michael
- WINWARD, Christopher Paul
- Prokuristen
- MAY, Graham Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 35210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Craig Reeves
- Privilege Investments Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BIOCORE AD2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-01
- Letzte Einreichung: 2019-12-21
-
ELLOUGH AD PLANT LIMITED Firmenbeschreibung
- ELLOUGH AD PLANT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07475331. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.12.2010 registriert. ELLOUGH AD PLANT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BIOCORE AD2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35210" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor 36 Spital Square erreicht werden.
Jetzt sichern ELLOUGH AD PLANT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ellough Ad Plant Limited - 4th Floor 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
- 2010-12-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ELLOUGH AD PLANT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-22) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-21) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-21) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-15) - AP01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-02-25) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-02-25) - SH08
-
resolution (2016-02-25) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-20) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-08) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-08) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-08) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-08) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-06) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-15) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-12-08) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-20) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-09-19) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-21) - NEWINC