-
PREMIER SERVICE LIMITED - Trinity Works, Bourne End Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07473272
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Trinity Works
- Bourne End Lane
- Hemel Hempstead
- Hertfordshire
- HP1 2UJ
- England Trinity Works, Bourne End Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 2UJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- OWEN, Gareth
- OWEN, Kenneth Lyndon
- Prokuristen
- OWEN, Kenneth Lyndon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 33190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Owen Trading Ltd
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PETROTEC SERVICE AND INSTALLATION LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-29
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-05
- Letzte Einreichung: 2020-09-21
-
PREMIER SERVICE LIMITED Firmenbeschreibung
- PREMIER SERVICE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07473272. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2010 registriert. PREMIER SERVICE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PETROTEC SERVICE AND INSTALLATION LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Trinity Works erreicht werden.
Jetzt sichern PREMIER SERVICE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Premier Service Limited - Trinity Works, Bourne End Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2010-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREMIER SERVICE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-15) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-06-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-17) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-27) - CS01
-
auditors-resignation-company (2019-08-06) - AUD
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-07-08) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-08) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-07-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-03) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-06-28) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-05-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-10-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-04-26) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
-
mortgage-create-with-deed (2014-08-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-03) - AR01
-
legacy (2013-03-22) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-04) - AR01
-
change-of-name-notice (2012-07-05) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2012-07-05) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-08-28) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-12) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-08-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
certificate-change-of-name-company (2011-07-28) - CERTNM
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-07-12) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-12-29) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-12-29) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2010-12-21) - CERTNM
-
incorporation-company (2010-12-20) - NEWINC