-
SMART IPX LTD - 5th Floor Grove House, 248a Marylebone Road, London, NW1 6BB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07460458
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor Grove House
- 248a Marylebone Road
- London
- NW1 6BB 5th Floor Grove House, 248a Marylebone Road, London, NW1 6BB UK
Management
- Geschäftsführung
- TINDLEY, Carol Ann
- TINDLEY, Paul Kendrick
- Prokuristen
- TINDLEY, Paul Kendrick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.12.2010
- Gelöscht am:
- 2023-08-04
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kim John Craven
- Mr Paul Kendrick Tindley
- Mrs Carol Ann Tindley
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-27
- Letzte Einreichung: 2020-02-13
-
SMART IPX LTD Firmenbeschreibung
- SMART IPX LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07460458. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor Grove House erreicht werden.
Jetzt sichern SMART IPX LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smart Ipx Ltd - 5th Floor Grove House, 248a Marylebone Road, London, NW1 6BB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMART IPX LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-05-04) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-08-04) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-07-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-05-28) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-28) - 600
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-08) - TM01
-
resolution (2020-05-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-07-07) - RP04
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-06-27) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-03-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-08-16) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-20) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-30) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-03-29) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2011-03-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-29) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-06) - NEWINC